www.wikidata.de-de.nina.az
Die Liste der Eintrage im National Register of Historic Places im Union County in Kentucky fuhrt die Bauwerke und historischen Statten im Union County auf die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden 1 Lage des Union County in Kentucky 2 Name 3 Bild Eintragsdatum Lage Ort Beschreibung1 Camp Breckinridge Non Commissioned Officers Club Camp Breckinridge Non Commissioned Officers Club 2001 ID Nr 01000804 1116 North Village Road 37 40 40 N 87 53 17 W 37 677778 87 888056Morganfield2 Confederate Monument of Morganfield Confederate Monument of Morganfield 1997 ID Nr 97000666 West Bannon Street und South Townsend Street auf dem stadtischen Friedhof 37 41 38 N 87 54 46 W 37 693889 87 912778Morganfield3 Daniel H Hughes House Daniel H Hughes House 1980 ID Nr 80001673 213 W O Bannon Street 37 41 2 N 87 55 9 W 37 683889 87 919167Morganfield4 Morganfield Commercial District Morganfield Commercial District 1984 ID Nr 84002063 Abgegrenzt durch Main Street Court Street und Morgan Street 37 41 2 N 87 55 2 W 37 683889 87 917222Morganfield5 George N Proctor House George N Proctor House 1990 ID Nr 90001488 KY 1180 ostlich der Kreuzung mit der Proctor Road 37 43 17 N 87 50 16 W 37 721389 87 837778Waverly6 Saline Island Saline Island 1998 ID Nr 98001291 Ohio River Flussmeilen 865 67 37 34 49 N 88 8 2 W 37 580278 88 133889Saline Mines7 Union County Courthouse Union County Courthouse 1978 ID Nr 78001401 Main Street 37 41 1 N 87 55 2 W 37 683611 87 917222MorganfieldSiehe auch BearbeitenListe der National Historic Landmarks in Kentucky National Register of Historic Places in KentuckyEinzelnachweise Bearbeiten Auszug aus dem National Register of Historic Places Union County Abgerufen am 31 August 2012 Die Nummerierung in dieser Listenspalte ist an der vom National Park Service vorgelegten Reihenfolge der Eintrage orientiert die Farben unterscheiden verschiedene Schutzgebietstypen des Nationalparksystems mit landesweiter Bedeutung z B National Historic Landmarks von den sonstigen Eintragen im National Register of Historic Places National Register Information System In National Register of Historic Places National Park Service abgerufen am 9 Juli 2010 englisch Eintrage im National Register of Historic Places in Kentucky National Register of Historic Places in KentuckyAdair Allen Anderson Ballard Barren Bath Bell Boone Bourbon Boyd Boyle Bracken Breathitt Breckinridge Bullitt Butler Caldwell Calloway Campbell Carlisle Carroll Carter Casey Christian Clark Clay Clinton Crittenden Cumberland Daviess Edmonson Elliott Estill Fayette Fleming Floyd Franklin Fulton Gallatin Garrard Grant Graves Grayson Green Greenup Hancock Hardin Harlan Harrison Hart Henderson Henry Hickman Hopkins Jackson Jefferson Jessamine Johnson Kenton Knott Knox LaRue Laurel Lawrence Lee Leslie Letcher Lewis Lincoln Livingston Logan Lyon Madison Magoffin Marion Marshall Martin Mason McCracken McCreary McLean Meade Menifee Mercer Metcalfe Monroe Montgomery Morgan Muhlenberg Nelson Nicholas Ohio Oldham Owen Owsley Pendleton Perry Pike Powell Pulaski Robertson Rockcastle Rowan Russell Scott Shelby Simpson Spencer Taylor Todd Trigg Trimble Union Warren Washington Wayne Webster Whitley Wolfe Woodford Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Liste der Eintrage im National Register of Historic Places im Union County Kentucky amp oldid 238504444