www.wikidata.de-de.nina.az
Die Liste der Registered Historic Places im Montgomery County fuhrt alle Bauwerke und historischen Statten im Montgomery County in Alabama auf die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden Inhaltsverzeichnis 1 Aktuelle Eintrage 2 Siehe auch 3 Weblinks 4 AnmerkungenAktuelle Eintrage BearbeitenLfd Nr Name Bild Datum der Eintragung Adresse Lage Ort ID Nr Beschreibung1 Alabama State Capitol nbsp 15 Okt 1966 Goat Hill Ostende der Dexter Ave Montgomery 66000152 Hat ausserdem den Status eines National Historic Landmarks 1 2 Alabama State University Historic District nbsp 8 Okt 1998 915 S Jackson St Montgomery 980012283 Bell Building nbsp 15 Dez 1981 207 Montgomery St Montgomery 810001324 Brame House 17 Sep 1980 402 404 S Hull St Montgomery 800007285 Building 800 Austin Hall nbsp 2 Marz 1988 Second St Maxwell AFB Montgomery 870021786 Building 836 Community College of the Air Force Building nbsp 2 Marz 1988 Maxwell Blvd Maxwell AFB Montgomery 870021827 Cassimus House nbsp 13 Aug 1976 110 N Jackson St Montgomery 760003498 City of St Jude Historic District nbsp 18 Juni 1990 2048 W Fairview Ave Montgomery 900009169 Cleveland Court Apartments 620 638 nbsp 29 Okt 2001 620 638 Cleveland Ct Montgomery 0100116710 Cloverdale Historic District nbsp 12 Sep 1985 grob begrenzt durch Norman Bridge und Cloverdale Rd Fairview Ave und Felder Av sowie Boultier St Montgomery 8500216111 Cottage Hill Historic District nbsp 7 Nov 1976 grob begrenzt durch Goldthwaite Bell Holt und Clayton St Montgomery 7600035012 Court Square Historic District nbsp 1 Marz 1982 21 35 Court St 1 2 Dexter Ave 18 24 N Court St und Court Sq Montgomery 8200206213 Court Square Dexter Avenue Historic District Boundary Increase 30 Aug 1984 grob entlang Dexter Ave Perry Court und Monroe St Montgomery 8400069714 Dexter Avenue Baptist Church nbsp 1 Juli 1974 454 Dexter Ave Montgomery 74000431 Hat ausserdem den Status eines National Historic Landmarks 2 15 Dexter Avenue Baptist Church 10 Marz 1982 309 S Jackson St Montgomery 8200206416 Dowe Historic District nbsp 29 Dez 1988 320 und 334 Washington Ave sowie 114 116 S Hull St Montgomery 8800307617 Dr C A Thigpen House nbsp 13 Dez 1977 1412 S Perry St Montgomery 7700021518 Edgewood nbsp 24 Apr 1973 3175 Thomas Ave Montgomery 7300036719 First White House of the Confederacy nbsp 25 Juni 1974 644 Washington Ave Montgomery 7400043220 Garden District nbsp 13 Sep 1984 grob begrenzt von Norman Bridge Rd Court St Jeff Davis Ave und Fairview Aves Montgomery 8400069821 Gay House nbsp 15 Marz 1975 230 Noble Ave Montgomery 7500032522 Gerald Dowdell House nbsp 28 Apr 1980 405 S Hull St Montgomery 8000072923 Gov Thomas G Jones House 8 Dez 1978 323 Adams Ave Montgomery 7800050624 Governor s Mansion nbsp 3 Juli 1972 1142 S Perry St Montgomery 7200017225 Grace Episcopal Church nbsp 19 Feb 1982 Pike Rd Mount Meigs 8200206726 Harrington Archaeological Site 25 Jan 1979 Adresse Verschlusssache Montgomery 7900039427 Huntingdon College Campus Historic District nbsp 24 Feb 2000 1500 E Fairview Ave Montgomery 0000013828 Jefferson Davis Hotel nbsp 13 Marz 1979 Ecke Catoma St und Montgomery Sts Montgomery 7500032429 Jefferson Franklin Jackson House nbsp 17 Mai 1984 409 S Union St Montgomery 8400071130 Jere Shine Site 8 Dez 1978 Adresse Verschlusssache Montgomery 7800050731 Lower Commerce Street Historic District nbsp 25 Feb 1982 grob begrenzt durch die Bahnstrecke N Court Commerce Coosa und Tallapoosa St Montgomery 8200206332 Maxwell Air Force Base Senior Officer s Quarters Historic District nbsp 2 Marz 1988 West Dr N Juniper St amp S Juniper St Inner Circle Center Dr Sequoia Dr East Dr auf der Maxwell Air Force Base Montgomery 8700217733 McBryde Screws Tyson House nbsp 28 Nov 1980 433 Mildred St Montgomery 8000073034 Montgomery Greyhound Bus Station nbsp 16 Mai 2011 210 S Court St Montgomery 1100029835 Montgomery Union Station and Trainshed nbsp 24 Juli 1973 Water St Montgomery 73000368 Hat ausserdem den Status eines National Historic Landmarks 3 36 Mt Zion AME Zion Church nbsp 4 Okt 2002 467 Holt St Montgomery 0200106637 Muklassa 28 Aug 1973 Adresse Verschlusssache Montgomery 7300036938 Old Ship African Methodist Episcopal Zion Church nbsp 24 Jan 1991 483 Holcombe St Montgomery 9000217739 Opp Cottage nbsp 4 Mai 1976 33 W Jefferson Davis Ave Montgomery 7600035140 Ordeman Shaw Historic District nbsp 13 Mai 1971 grob begrenzt durch McDonough Decatur Madison und Randolph St Montgomery 7100010541 Patrick Henry Brittan House nbsp 13 Dez 1979 507 Columbus St Montgomery 7900039342 Pepperman House nbsp 1 Marz 1982 17 Mildred St Montgomery 8200206543 Perry Street Historic District nbsp 16 Dez 1971 grob begrenzt durch McDonough St im Osten Sayre St im Westen Washington St im Norden und Donaldson St im Suden Montgomery 7100010644 Powder Magazine nbsp 13 Apr 1973 am Ende der Eugene St Montgomery 7300037045 Sayre Street School nbsp 19 Feb 1982 506 Sayre St Montgomery 8200206646 Scott Street Firehouse nbsp 12 Feb 1981 418 Scott St Montgomery 8100013347 Semple House nbsp 27 Sep 1972 725 Monroe St Montgomery 7200017448 Shepherd Building nbsp 22 Mai 1986 312 Montgomery St Montgomery 8600110649 Smith Joseph Stratton House nbsp 11 Apr 1985 302 Alabama St Montgomery 8500073650 South Perry Street Historic District nbsp 30 Aug 1984 grob entlang der Perry St zwischen Washington St und Dexter Ave Montgomery 8400071351 St John s Episcopal Church nbsp 24 Feb 1975 113 Madison Ave Montgomery 7500032652 Stay House nbsp 10 Sep 1979 631 S Hull St Montgomery 7900039653 Steiner Lobman and Teague Hardware Buildings nbsp 31 Jan 1979 184 and 172 Commerce St Montgomery 7900039754 Stone Plantation nbsp 31 Dez 2001 5001 Old Selma Rd Montgomery 0100141155 Tankersley Rosenwald School nbsp 22 Jan 2009 Hope Hull 0800133256 The Murphy House nbsp 24 Marz 1972 22 Bibb St Montgomery 7200017357 Tulane Building nbsp 21 Marz 1979 800 High St Montgomery 7900039858 Tyson Maner House nbsp 10 Mai 1979 469 S McDonough St Montgomery 7900039959 United States Post Office and Courthouse Montgomery 3 Juni 1998 Church St zwischen Moulton und Lee St Montgomery 98000611 Hat ausserdem den Status eines National Historic Landmarks 4 60 Winter Building nbsp 14 Jan 1972 2 Dexter Ave Montgomery 7200017561 Winter Place nbsp 31 Mai 2006 454 S Goldwaite St Montgomery 0600043962 William Lowndes Yancey Law Office nbsp 7 Nov 1973 Ecke Adams St und Perry St Montgomery 73000371Siehe auch BearbeitenListe der National Historic Landmarks in Alabama National Register of Historic Places in AlabamaWeblinks BearbeitenSuchmaske Datenbank im National Register Information System National Park ServiceAnmerkungen Bearbeiten Listing of National Historic Landmarks by State Alabama National Park Service abgerufen am 5 April 2020 Listing of National Historic Landmarks by State Alabama National Park Service abgerufen am 2 April 2020 Listing of National Historic Landmarks by State Alabama National Park Service abgerufen am 2 April 2020 Listing of National Historic Landmarks by State Alabama National Park Service abgerufen am 2 April 2020 Eintrage im National Register of Historic Places im US Bundesstaat Alabama National Register of Historic Places in AlabamaAutauga Baldwin Barbour Bibb Blount Bullock Butler Calhoun Chambers Cherokee Chilton Choctaw Clarke Clay Cleburne Coffee Colbert Conecuh Coosa Covington Crenshaw Cullman Dale Dallas DeKalb Elmore Escambia Etowah Fayette Franklin Geneva Greene Hale Henry Houston Jackson Jefferson Lamar Lauderdale Lawrence Lee Limestone Lowndes Macon Madison Marengo Marion Marshall Mobile Monroe Montgomery Morgan Perry Pickens Pike Randolph Russell Shelby St Clair Sumter Talladega Tallapoosa Tuscaloosa Walker Washington Wilcox Winston Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Liste der Eintrage im National Register of Historic Places im Montgomery County Alabama amp oldid 237785346